Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 10/1/2022 - Empresarios
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 5
Lunes 10 de enero de 2022
Pág. 869
SECCIÓN PRIMERA
Empresarios Actos inscritos ALICANTE/ALACANT
8172 - PAJARES SALINAS SL.
Ampliación de capital. Capital: 2.404,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.988.236,00 Euros. Datos registrales. T 1990 , F 28, S 8, H A
41514, I/A 8 27.12.21.
8173 - BONALBA 2000 SA.
Ceses/Dimisiones. Consejero: GRUPO ALICANTE URBANA DESARROLLO SL. Vicepresid.: GRUPO ALICANTE URBANA
DESARROLLO SL. Cons.Del.Sol: GRUPO ALICANTE URBANA DESARROLLO SL. Revocaciones. Apo.Sol.: GALLEGO TOLEDO
ENRIQUE;FERNANDEZ BASTIDA ENRIQUE. Nombramientos. Apo.Sol.: LE ROUX JEAN PAUL CHARLES;DARBLADE XAVIER
OSWALD JEAN. Datos registrales. T 4347 , F 146, S 8, H A 26497, I/A 26 30.12.21.
8174 - CUMNOCK SA.
Reducción de capital. Importe reducción: 100.370,34 Euros. Resultante Suscrito: 1.131.720,66 Euros. Reducción de capital.
Importe reducción: 310.017,12 Euros. Resultante Suscrito: 821.703,54 Euros. Datos registrales. T 2183 , F 220, S 8, H A 2661, I/A 10
28.12.21.
8175 - HIJOS DE ENRIQUE GARRIGOS SL.
Ceses/Dimisiones. Liquidador: GARRIGOS DE LA UZ ENRIQUE. Extinción. Datos registrales. T 2697 , F 116, S 8, H A 79103, I/A
7 28.12.21.
8176 - GROUP XXI ELCHE SL.
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MOLINA CORTES JUAN PEDRO. Datos registrales. T 4401 , F 67, S 8, H A 175747, I/A 2 29.12.21.
8177 - LOGAJAX SL.
Ampliacion del objeto social. 7311 Agencias de Publicidad. Cambio de domicilio social. C/ DEL MAR 34 1 IZ - PARTIDA DE EL
ALTET ELCHE. Datos registrales. T 4280 , F 159, S 8, H A 168970, I/A 2 29.12.21.
8178 - RESTAURANTE CLUB DE TENIS ALICANTE SL.
Ceses/Dimisiones. Liquidador: PASCUAL GRIMALDOS FRANCISCA. Adm. Unico: BODOLAI JOSEF PEDER. Nombramientos.
Liquidador: PASCUAL GRIMALDOS FRANCISCA. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 2968 , F 67, S 8, H A
94248, I/A 2 29.12.21.
8179 - PLAYA Y CIELO SL.
Nombramientos. Auditor: GEAUDIT AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4232 , F 5, S 8, H A 50338, I/A 23 30.12.21.
8181 - TERRA MITICA, PARQUE TEMATICO DE BENIDORM SA.
Nombramientos. Auditor: GEAUDIT AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2790 , F 75, S 8, H A 46268, I/A 113 30.12.21.
8182 - AGROBELDI TRACTORES SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 13.12.21. Objeto social: Actividades de apoyo a la agricultura. Domicilio: C/ FRANCISCO
TARRUELLA 6 1 IZ VILLENA. Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: BELDA HERNANDEZ
RAUL. Nombramientos. Adm. Unico: BELDA HERNANDEZ RAUL. Datos registrales. T 4432 , F 182, S 8, H A 177590, I/A 1
30.12.21.
8183 - TRANSPORTES JUANPI SL.
Cambio de domicilio social. C/ ESCULTOR GUTIERREZ 7 Bl.I Esc.A 1 B ALICANTE. Datos registrales. T 1339 , F 141, S 8, H A
cve: BORME-A-2022-5-03
Verificable en https www.boe.es
8180 - MARMOLES PULYCORT SL.
Cambio de domicilio social. CTRA NOVELDA-LA ROMANA Km 8 ROMANA LA. Cambio de objeto social. 2.- Actividades administrativas y auxiliares de oficina. Así como la comercialización e intermediación en cualquier tipo de operación. Datos registrales. T 2018 , F 54, S 8, H A 42928, I/A 13 29.12.21.