Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 21/12/2018 - Empresarios

Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 244

Viernes 21 de diciembre de 2018

Pág. 54842

SECCIÓN PRIMERA
Empresarios Actos inscritos ALICANTE

511018 - JUAN CORTELL SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORTELL BLASCO JOSE RAFAEL. Nombramientos. Adm. Unico: CORTELL BLASCO JUAN.
Datos registrales. T 3948 , F 216, S 8, H A 150242, I/A 3 11.12.18.
511019 - MINILAND NEW CONCEPTS SA.
Ceses/Dimisiones. Presidente: SEMPERE FERRI GERMAN. Vicepresid.: SEMPERE GUTIERREZ FERRAN. Secretario: SEMPERE
GARCIA CAYO. Cons.Del.Sol: SEMPERE FERRI GERMAN;VERDU FRANCES JOSE. Nombramientos. Presidente: SEMPERE
GARCIA CAYO. Vicepresid.: SEMPERE FRANCES JORGE. Secretario: SEMPERE GUTIERREZ FERRAN. Con.Delegado: VERDU
FRANCES JOSE. Reelecciones. Consejero: SEMPERE FERRI GERMAN;SEMPERE GARCIA CAYO;SEMPERE GUTIERREZ
FERRAN;SEMPERE FRANCES JORGE;VERDU FRANCES JOSE. Otros conceptos: Modificación de la totalidad de los estatutos sociales.- Datos registrales. T 3751 , F 25, S 8, H A 21891, I/A 16 12.12.18.
511020 - PROYECTOS Y EJECUCIONES SOCIEDAD ANONIMA.
Ceses/Dimisiones. Presidente: SEMPERE FERRI GERMAN. Vicepresid.: SEMPERE GUTIERREZ FERRAN. Secretario: SEMPERE
GARCIA CAYO. Cons.Del.Man: SEMPERE FERRI GERMAN;VERDU FRANCES JOSE. Nombramientos. Presidente: SEMPERE
GARCIA CAYO. Vicepresid.: SEMPERE FRANCES JORGE. Secretario: SEMPERE GUTIERREZ FERRAN. Con.Delegado: VERDU
FRANCES JOSE. Reelecciones. Consejero: SEMPERE FERRI GERMAN;SEMPERE GARCIA CAYO;SEMPERE GUTIERREZ
FERRAN;SEMPERE FRANCES JORGE;VERDU FRANCES JOSE. Otros conceptos: Modificación de la totalidad de los estatutos sociales.- Datos registrales. T 3748 , F 180, S 8, H A 24108, I/A 11 12.12.18.
511021 - CHEF MAESTRO HORECA SL.
Revocaciones. Apo.Sol.: FERRANDO APARICIO ALBA. Datos registrales. T 4001 , F 215, S 8, H A 134891, I/A 13 13.12.18.
511022 - MOBEL COMERCIAL PLANET SL.
Nombramientos. Apoderado: PARRES JUAN DAVID. Datos registrales. T 3694 , F 38, S 8, H A 135242, I/A 3 13.12.18.
511023 - INVERGEST BONET SL.
Ampliación de capital. Capital: 75.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.090.000,00 Euros. Datos registrales. T 3824 , F 121, S 8, H
A 142996, I/A 3 13.12.18.
511024 - EUROMAR IMPEX SL.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: MATOS ESPINAL YUDELKA. Datos registrales. T 4126 , F 56, S 8, H A 160132, I/A 2 13.12.18.

511026 - MINILAND SOCIEDAD ANONIMA.
Ceses/Dimisiones. Presidente: SEMPERE FERRI GERMAN. Vicepresid.: SEMPERE GUTIERREZ FERRAN. Secretario: SEMPERE
GARCIA CAYO. Cons.Del.Sol: SEMPERE FERRI GERMAN;VERDU FRANCES JOSE. Nombramientos. Presidente: SEMPERE
GARCIA CAYO. Vicepresid.: SEMPERE FRANCES JORGE. Secretario: SEMPERE GUTIERREZ FERRAN. Con.Delegado: VERDU
FRANCES JOSE. Reelecciones. Consejero: SEMPERE FERRI GERMAN;SEMPERE GARCIA CAYO;SEMPERE GUTIERREZ
FERRAN;SEMPERE FRANCES JORGE;VERDU FRANCES JOSE. Otros conceptos: Modificación de la totalidad de los estatutos sociales.- Datos registrales. T 3749 , F 210, S 8, H A 21889, I/A 16 13.12.18.
511027 - BORJA TRUCKS SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 26.10.18. Objeto social: la distribución, venta, fabricación de toda clase de vehículos, maquinaría, herramientas, respuestos y accesorios de todo tipo, industrial, agrícola, turismo, así como talleres de reparación y montaje
cve: BORME-A-2018-244-03

511025 - AMANA & DELIGHT SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 13.11.18. Objeto social: La producción y elaboración de todo tipo de productos cárnicos y sus derivados. La venta y comercialización de productos cárnicos y sus derivados, así como la exportación e importación de productos cárnicos y sus derivados, así como la exportación e importación de materias primas y productos elabor. Domicilio: AVDA DE
MAISONNAVE 27 7º B ALICANTE. Capital: 3.500,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: ABBOU HAFID. Datos registrales. T
4173 , F 200, S 8, H A 162905, I/A 1 13.12.18.

About this edition

Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 21/12/2018 - Empresarios

TitleBoletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

CountrySpain

Date21/12/2018

Page count239

Edition count3275

First edition03/01/2011

Last issue14/05/2024

Download this edition

Other editions

<<<Diciembre 2018>>>
DLMMJVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031