Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 23/10/2018 - Empresarios

Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 204

Martes 23 de octubre de 2018

Pág. 45333

421415 - ARIDOS BELI SL.
Revocaciones. Apoderado: MIRALLES PRIETO TOMAS. Datos registrales. T 3651 , F 59, S 8, H A 132651, I/A 3 15.10.18.
421416 - DALLAGLIO DENTAL SLP.
Nombramientos. Apoderado: DALLAGLIO HERNAN. Datos registrales. T 3350 , F 64, S 8, H A 115664, I/A 2 15.10.18.
421417 - AGROCAÑIZARES SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 4.10.18. Objeto social: La producción y comercialización de hortalizas, hierbas aromáticas, frutas y verduras. Domicilio: CTRA RAFAL-ALMORADI, CV-912 Km 2,5 - PEDANIA DEL M ORIHUELA. Capital: 3.050,00 Euros.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: LOPEZ CAÑIZARES MONSERRATE. Nombramientos. Adm. Unico: LOPEZ
CAÑIZARES MONSERRATE. Datos registrales. T 4159 , F 127, S 8, H A 162075, I/A 1 15.10.18.
421418 - ANTHOPHILA REHABILITACIONES SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 17.09.18. Objeto social: la promoción, construcción, arrendamiento y compraventa de todo tipo de inmuebles. Domicilio: C/ SERRANO 5 LOCAL ALICANTE. Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico:
HERNANDEZ PERALES MATIAS PEDRO. Datos registrales. T 4159 , F 123, S 8, H A 162073, I/A 1 15.10.18.
421419 - BANCO DE SABADELL SA.
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLANCO BORRAS IGNACIO;GARCIA HERMOSO PAULA MARIA;BELLIDO DE LA TORRE
MANUEL;MATIAS DELICADO ANA;ALPUENTE PRADAS ANTONIO;FONSECA GRANDA CARMEN;PARRAGA FERNANDEZ
MARCOS JUAN;LOZANO SAIZ VANESSA;BEJARANO JIMENEZ SANDRA;RIBAS VILA VANESSA;DEL OLMO ABRIL
ALEJANDRO;ORTS LAZA VICENTE FRANCISCO;ALMENDROS MOHINO RICARDO;CORDOMI SOMS JORDI. Datos registrales.
T 4070 , F 52, S 8, H A 156980, I/A 78 15.10.18.
421420 - RECUPERACIONES Y DESGUACES TOLON SA.
Reelecciones. Adm. Unico: TOLON SANCHEZ RICARDO. Datos registrales. T 3332 , F 51, S 8, H A 5128, I/A 16 15.10.18.
421421 - WAN. HAO COMPLEMENTOS SL.
Cambio de domicilio social. C/ CASTAÑOS 43 1º DC ALICANTE. Datos registrales. T 4160 , F 132, S 8, H A 162076, I/A 2
15.10.18.
421422 - ESTACION NAUTICA SL.
Nombramientos. Apoderado: SENDRA ARNAU MARIA ANGELES. Datos registrales. T 2386 , F 46, S 8, H A 61784, I/A 4
15.10.18.
421423 - CONSTRUCCIONES DANDI VEGA BAJA SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 5.10.18. Objeto social: La compraventa de bienes inmuebles. La promoción, marketing, comercialización, administración, construcción, y urbanización de edificios con destino a locales comerciales, viviendas, plazas de aparcamiento, garajes, hoteles, restaurantes, bares, pubs, cafeterías, salas de espectáculos, y de su explo. Domicilio: C/ ORIHUELA
22 JACARILLA. Capital: 5.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: ALFOCEA SOLER JOSE MANUEL.
Nombramientos. Adm. Unico: ALFOCEA SOLER JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4160 , F 135, S 8, H A 162078, I/A 1
15.10.18.
421424 - LOST PARADISES SL.
Cambio de domicilio social. C/ PINTOR LORENZO CASANOVA 46 ENTLO ALICANTE. Datos registrales. T 2989 , F 60, S 8, H
A 95389, I/A 4 15.10.18.

421426 - ELFA AVENTURE SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 20.09.18. Objeto social: Servicios de asistencia a los turistas, intérpretes y promoción turística, así como también comercio al por menor de muñecas y juguetes. Domicilio: C/ FAVANELLA 30 ONIL. Capital: 4.000,00
Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: VILCHEZ JUAN ELIZABET. Nombramientos. Adm. Unico: VILCHEZ JUAN
ELIZABET. Datos registrales. T 4159 , F 142, S 8, H A 162083, I/A 1 15.10.18.
421427 - INFOTECH FALSERR ALICANTE SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 4.10.18. Objeto social: El comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y telecomunicaciones, venta de ordenadores, terminales de telefonía fija y móvil y distribución de internet. El comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y telecomunicaciones, venta de ordenadore. Domicilio: C/ POETA
CAMPOS VASALLO 52 2º ALICANTE. Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: FALCO SERRANO

cve: BORME-A-2018-204-03

421425 - SINERGIA 3000 SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCIA JAVALOYES HILARIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: GARCIA JAVALOYES
HILARIO;GARCIA JAVALOYES JOSE ANTONIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 3569 , F 112, S 8, H A 127905, I/A 4 15.10.18.

About this edition

Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 23/10/2018 - Empresarios

TitleBoletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

CountrySpain

Date23/10/2018

Page count229

Edition count3275

First edition03/01/2011

Last issue14/05/2024

Download this edition

Other editions

<<<Octubre 2018>>>
DLMMJVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031