Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 15/10/2018 - Empresarios

Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 198

Lunes 15 de octubre de 2018

Pág. 44182

SECCIÓN PRIMERA
Empresarios Actos inscritos ALICANTE

410747 - GESTION EMPRESARIAL Y CONSULTING SA.
Fe de erratas: Rectificada la inscripción 10 en cuanto a la fecha de reelección de la administradora única -30 de junio de 2016- y la de terminación de -30 de junio de 2021- siendo la fecha correcta de dicha reelección el 30 de junio de 2018 y la de terminación 30 de junio de 2023.- Datos registrales. T 1579 , F 187, S 8, H A 20423, I/A 10 1.08.18.
410748 - ELCHE CLUB DE FUTBOL SAD.
Ceses/Dimisiones. Consejero: OLIVER LAZARO JAIME SALVADOR;SANCHEZ MATEOS FRANCISCO MANUEL;HELIKE
FOOTBAL MANAGEMENT SL;MARUENDA SANCHIS JOSE LUIS;NOHALES HERRAIZ CESAR;SEGARRA ANIORTE RAMON
JOSE;MOXICA PRUNEDA PASCUAL;MESEGUER GARCIA FRANCISCO VICENTE. Presidente: HELIKE FOOTBAL MANAGEMENT
SL. Secretario: SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE. Nombramientos. Consejero: MOXICA PRUNEDA PASCUAL;MESEGUER
GARCIA FRANCISCO VICENTE;GARCIA JUAN DIEGO;SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE;MARUENDA SANCHIS JOSE LUIS.
Presidente: GARCIA JUAN DIEGO. Secretario: SEGARRA ANIORTE RAMON JOSE. Apo.Manc.: GARCIA JUAN DIEGO;SEGARRA
ANIORTE RAMON JOSE;MARUENDA SANCHIS JOSE LUIS. Consejero: MESEGUER GARCIA FRANCISCO VICENTE;MOXICA
PRUNEDA PASCUAL. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 21º.- Composición y nombramiento del consejo de Administración.. Datos registrales. T 3709 , F 208, S 8, H A 42149, I/A 90 3.10.18.
410749 - COSTUMBRES GASTRONOMICAS SL.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: D.T.Y. SUROESTE SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALCAHUZ FERNANDEZ
JOSE. Nombramientos. Adm. Solid.: ALCAHUZ VILLAVERDE VICTOR;ALCAHUZ VILLAVERDE GABRIEL. Otros conceptos:
Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios. Cambio de objeto social. el transporte de mercancías por carretera. También podrá dedicarse la sociedad al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia; y a la compraventa de inmuebles y servicios de hostelería. Datos registrales. T 2554 , F 144, S 8, H A 71220, I/A 7 2.10.18.
410750 - ESPHOUSES INVERSIONES INMOBILIARIAS SL.
Reducción de capital. Importe reducción: 2.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.000,00 Euros. Ampliación de capital. Capital:
1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Datos registrales. T 3903 , F 19, S 8, H A 147481, I/A 2 3.10.18.
410751 - FORRADOS Y APARADOS LUNA SL.
Constitución. Comienzo de operaciones: 14.09.18. Objeto social: Taller auxiliar de calzado. Domicilio: PTDA LLANO DE SAN JOSE
86 ELCHE. Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: HERNANDEZ MIRALLES MANUEL MIGUEL.
Nombramientos. Adm. Unico: HERNANDEZ MIRALLES MANUEL MIGUEL. Datos registrales. T 4157 , F 140, S 8, H A 161961, I/A
1 3.10.18.
410752 - MULA & TARANCON INMUEBLES SL.
Cambio de domicilio social. CTRA DE BENIEL Km 1,100 ORIHUELA. Cambio de objeto social. INTERMEDIACION. objeto principal: El alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, CNAE 6820. También tiene por objeto: 1.- Dirigir y gestionar la participación de la Sociedad en el capital social de otras entidades mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales, pu. Datos registrales. T 3088 , F 35, S 8, H A 100954, I/A 2 3.10.18.

410754 - VIDEAC SA.
Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ OCAÑA MARIA VICENTA. Apo.Manc.: COBO BUXENS ALVARO. Apo.Sol.: COBO BUXENS
ALVARO. Apo.Manc.: GARCIA PEREZ JUAN JOSE. Apo.Sol.: GARCIA PEREZ JUAN JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli:
GARCIA PEREZ JUAN JOSE;MENENDEZ DEL CAMPO IGNACIO. Apo.Manc.: ZURITA VILLAFRANCA LUIS. Apo.Sol.: PEREZ
OCAÑA MARIA VICENTA. Apo.Man.Soli: RUBIO ALCARRIA MARIA ENCARNACION. Datos registrales. T 3975 , F 68, S 8, H A
100525, I/A 34 3.10.18.
410755 - ORDENIA SL.
Declaración de unipersonalidad. Socio único: RODRIGUEZ WINLOW ELISA. Datos registrales. T 3420 , F 84, S 8, H A 119554,
cve: BORME-A-2018-198-03

410753 - P&G INVESTMENTS NOVA DOMUS SL.
Ampliación de capital. Capital: 310.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 313.000,00 Euros. Datos registrales. T 3963 , F 99, S 8, H A
150985, I/A 2 3.10.18.

About this edition

Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 15/10/2018 - Empresarios

TitleBoletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Empresarios

CountrySpain

Date15/10/2018

Page count153

Edition count3273

First edition03/01/2011

Last issue08/05/2024

Download this edition

Other editions

<<<Octubre 2018>>>
DLMMJVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031